法蘭克·洛伊·萊特作品列表

維基媒體列表條目

美國建築師法蘭克·洛伊·萊特一生完成了許多的建築設計,本列表收錄了超過 415 項作品。

圖表標示编辑

已拆除或毀壞。

對一般大眾開放。

存在爭議的作品。(未經證實為法蘭克·洛伊·萊特的作品。)

作品列表编辑

法蘭克·洛伊·萊特完成的作品
名稱城市州/國家設計時間建造時間備註圖片
聯合禮拜堂春綠村威斯康辛州1886年1886年約瑟夫·萊曼·席爾斯比合作。
Hillside Home School I春綠村威斯康辛州1887年1887年約瑟夫·萊曼·席爾斯比合作。
1950年拆除。
萊特之家橡樹園伊利諾州1889年1889年1895年增加廚房和遊戲間。
1911年改建。
1974-1987年整修。
William Storrs MacHarg House芝加哥伊利諾州1890年1891年1903年由路易斯·沙利文改建。
1926年拆除。
路易斯·沙利文小屋海泉市密西西比州1890年1890年颶風卡崔娜所摧毀。
James A. Charnley Bungalow海泉市密西西比州1890年1890年2005年受到颶風卡崔娜重創。(照片)
2009年進行整修。 (照片)页面存档备份,存于互联网档案馆
James A. Charnley House芝加哥伊利諾州1891年1892年路易斯·沙利文合作。
Dr. Allison W. Harlan House[1]芝加哥伊利諾州1891年1892年1963年毀於火災。
Warren McArthur House[2]芝加哥伊利諾州1892年1892年1900年改建。
George Blossom House[3]芝加哥伊利諾州1892年1892年1907年增加車庫。
Robert G. Emmond House[4]拉格蘭奇伊利諾州1892年1892年
Thomas H. Gale House橡樹園伊利諾州1892年1892年
Robert P. Parker House橡樹園伊利諾州1892年1892年
Albert Sullivan House[5]芝加哥伊利諾州1892年1892年路易斯·沙利文合作。
1970年拆除。
W. Irving Clark House[6]拉格蘭奇伊利諾州1892年1893年
Walter H. Gale House橡樹園伊利諾州1893年1893年
Robert M. Lamp Cottage
(Rocky Roost)[7]
麥迪遜威斯康辛州1893年1893年1901年改建。
1934年毀於火災。
Lake Mendota Boathouse[8]麥迪遜威斯康辛州1893年1893年1926年拆除。
Francis J. Woolley House橡樹園伊利諾州1893年1893年
William H. Winslow HouseRiver Forest伊利諾州1893年1894年
Peter Goan House[9]拉格蘭奇伊利諾州1893年1894年
Robert W. Roloson Houses芝加哥伊利諾州1894年1894年
Frederick Bagley House[10]Hinsdale伊利諾州1894年1894年
Henry and Lily Mitchell HouseRacine威斯康辛州1894年1894年可能是塞西爾·科溫的作品[11]
,或為萊特與科溫合作。[12]
Dr. H. W. Bassett House[13]橡樹園伊利諾州1894年1894年1922年拆除。
Francisco Terrace Apartments[14]芝加哥伊利諾州1895年1895年1974年拆除
1977年外觀改建並遷移到橡樹園[15]
Edward C. Waller Apartments芝加哥伊利諾州1895年1895年其中一個單位1968年毀於火災。
Francis Apartments[16]芝加哥伊利諾州1895年1895年1971年拆除。
Chauncey L. Williams HouseRiver Forest伊利諾州1895年1895年
Nathan G. Moore House I橡樹園伊利諾州1895年1895年1922年部份毀於火災。
Rebuilt and redesigned 1923年重建並重新設計。
(請見Nathan Moore House II
Harrison P. Young House橡樹園伊利諾州1895年1895年Remodel
George W. Smith House橡樹園伊利諾州1895年1898年
羅密歐與茱麗葉風車[17]春綠村威斯康辛州1896年1896年1938年重建。
Isidore H. Heller House芝加哥伊利諾州1896年1897年
Harry C. Goodrich House[18]橡樹園伊利諾州1896年1896年
en:Charles E. Roberts House[19]橡樹園伊利諾州1896年1896年Remodel
Charles E. Roberts Stable橡樹園伊利諾州1896年1896年1903-05年改造成居住空間。
1929年遷移到現今地點。
George W. Furbeck House橡樹園伊利諾州1897年1897-98年
Rollin Furbeck House[20]橡樹園伊利諾州1897年1897年Remodeled 1907年
Thomas H. Gale CottageWhitehall密西根1897年
River Forest Golf Club[21]River Forest伊利諾州1898年已拆除。
萊特之家
(增建事務所)
橡樹園伊利諾州1897年1898年1905年內部及外部整修。
1911年改建。
1982-1987年進行修復。
Joseph and Helen Husser House[22]芝加哥伊利諾州1899年1926年拆除。
Edward C. Waller HouseRiver Forest伊利諾州1899年Remodel
1939年拆除。
William and Jessie M. Adams House芝加哥伊利諾州1900年1900-01年
S. A. Foster House and Stable芝加哥伊利諾州1900年1900年
B. Harley Bradley House
(Glenlloyd)[23]
Kankakee伊利諾州1900年
Warren Hickox HouseKankakee伊利諾州1900年1900年
E.H. Pitkin CottageSapper Island,[24] Desbarats, Ontario加拿大1900年
Henry Wallis CottageDelavan威斯康辛州1900年
Edward C. Waller Gates, Poultry House, and StablesRiver Forest伊利諾州1901年1939年拆除禽舍。
1970年代拆除馬廄。
Gate posts and fence reused as entrance to a modern subdivision
Fred B. Jones House
(Penwern)
Delavan威斯康辛州1901年1902年
Ward Winfield Willits HouseHighland Park伊利諾州1901年
F. B. Henderson HouseElmhurst伊利諾州1901年1901年
William G. Fricke House[25]橡樹園伊利諾州1901年
Buffalo Exposition Pavilion for the Universal Portland Cement Company[26]水牛城紐約1901年1901年暫時性建築。
已拆除。
Frank W. Thomas House橡樹園伊利諾州1901年1901年
E. Arthur Davenport House[27]River Forest伊利諾州1901年
William E. Martin House[28]橡樹園伊利諾州1902年
Lake Delavan Yacht Club[29]Delavan威斯康辛州1902年
Hillside Home School II春綠村威斯康辛州1902年
Francis W. Little House I[30]Peoria伊利諾州1902年1902年Stable added 1909年
Arthur B. Heurtley House橡樹園伊利諾州1902年1902年
Arthur B. Heurtley Summer HouseMarquette Island密西根1902年1902年Remodel
Mrs. George Gerts Double House, Bridge CottageWhitehall密西根1902年
Dana-Thomas HouseSpringfield伊利諾州1902年1902-04年
Walter Gertz Bridge CottageWhitehall密西根1902年
Alfred W. Hebert House芝加哥伊利諾州1902年Remodel
1959年部份因火災毀損。
所有萊特設計的物件都遷走重建。
George W. Spencer HouseDelavan威斯康辛州1902年
Charles S. Ross HouseDelavan威斯康辛州1902年
John A. Mosher HouseWellington俄亥俄州1902年1903-04年原先為Mosher設計蓋在維爾梅特(Willmette)的房子。
塔里耶森無此房舍的設計圖。[31]
許多萊特的作品集也沒有收錄這個作品。[32]
George F. Barton House水牛城紐約1902年1903-04年
Joseph J. Walser, Jr. House芝加哥伊利諾州1903年
Horse Show Fountain橡樹園伊利諾州1903年1909年1969年重建。
Abraham Lincoln Center[33]芝加哥伊利諾州1903年設計工作由德懷特·H·珀金斯(Dwight Perkins)完成。
Robert M. Lamp House麥迪遜威斯康辛州1903年1903年
Darwin D. Martin Carriage House, Conservatory, and Pergola水牛城紐約1903年1903年-051962年拆除。
2004-2007年重建。
Darwin D. Martin House水牛城紐約1903年1904-05年2004-2010年整修。
Edwin H. Cheney House橡樹園伊利諾州1903年
Larkin Administration Building水牛城紐約1904年1950年拆除。
Unity Temple橡樹園伊利諾州1904年1905-08年
Burton J. Westcott HouseSpringfield俄亥俄州1904年1908年
William R. Heath House水牛城紐約1904年1904-05年
Ferdinand F. Tomek House
(The Ship House)
Riverside伊利諾州1904年1904-06年
Harvey P. Sutton HouseMcCook內布拉斯加州1905年1905年
Hiram Baldwin HouseKenilworth伊利諾州1905年1905年
Mary W. Adams HouseHighland Park伊利諾州1905年1905年
William A. Glasner HouseGlencoe伊利諾州1905年1905年
Charles A. Brown House[34]Evanston伊利諾州1905
Frank L. Smith BankDwight伊利諾州1905年1905年
E. W. Cummings Real Estate OfficeRiver Forest伊利諾州19051925年拆除。
E-Z Polish Factory芝加哥伊利諾州1905年1905年
Lawrence Memorial LibrarySpringfield伊利諾州1905年
A. P. Johnson HouseDelavan威斯康辛州19051905
Thomas P. Hardy HouseRacine威斯康辛州1905年1905年
Darwin D. Martin Gardener’s Cottage水牛城紐約1905年1909年
Mrs Thomas H. Gale Cottage I, II & IIIWhitehall密西根1905年1909年
Rookery Building芝加哥伊利諾州1905年1907年Lobby remodeling
William H. Pettit Mortuary ChapelBelvidere伊利諾州1906年1907年
Peter A. Beachy House橡樹園伊利諾州1906年1906年Remodel
Frederick D. Nichols House[35]Flossmoor伊利諾州1906年
River Forest Tennis Club[36]River Forest伊利諾州1906年Moved[37] 1920年 to present location.
Edward R. Hills House橡樹園伊利諾州1906年1906年1977年火災後重建。
P. D. Hoyt HouseGeneva伊利諾州1906年
Mrs. A. W. Gridley House
(Ravine House)
Batavia伊利諾州1906年1906年
Grace Fuller HouseGlencoe伊利諾州1906年不確定是否曾建造。
K. C. DeRhodes HouseSouth Bend印第安納州1906年1906年
George M. Millard HouseHighland Park伊利諾州1906年1906年
Tan-Y-Deri
(Andrew T. Porter House)[38]
春綠村威斯康辛州1907年1907年Based on "A Fireproof House for $5000"
Avery Coonley HouseRiverside伊利諾州1907年Complex completed 1912年
Stephen M. B. Hunt House I拉格蘭奇伊利諾州1907年1907年Based on "A Fireproof House for $5000"
Col. George Fabyan VillaGeneva伊利諾州1907年1907年Remodel
Fox River Country ClubGeneva伊利諾州1907年Remodel
1910年毀於火災。
Larkin Company Exhibition PavilionJamestown維吉尼亞州1907年1907年暫時性建築,已拆除。
Pebbles & Balch Office橡樹園伊利諾州1907年1907年Remodel
1942年拆除。
羅比之家芝加哥伊利諾州1908年1909年-10
G. C. Stockman HouseMason City愛荷華州1908年1908年Based on "A Fireproof House for $5000"
Raymond W. Evans House芝加哥伊利諾州1908年
Browne’s Bookstore芝加哥伊利諾州1908年Interior design
Demolished 1912年 (redesigned for a new tenant)
L. K. Horner House[39]芝加哥伊利諾州1908年1952年拆除。
Eugene A. Gilmore House
(Airplane House)
麥迪遜威斯康辛州1908年1908年
Edward E. Boynton HouseRochester紐約1908年1908年
Walter V. Davidson House水牛城紐約1908年1908年
Isabel Roberts HouseRiver Forest伊利諾州1908年1908年
Meyer May HouseGrand Rapids密西根1908年1908年-09
William H. Copeland House橡樹園伊利諾州1908年1908年-09Garage 1908年
Remodel 1909年
City National Bank Building and Park Inn HotelMason City愛荷華州1908年-091909年-10
Edmund F. Brigham HouseGlencoe伊利諾州1908年–091915年
Mrs. Thomas H. Gale House橡樹園伊利諾州1909年1909年
Como Orchard Summer ColonyDarby蒙大拿州1909年
Bitter Root Inn[40]Stevensville蒙大拿州1909年Destroyed by fire 1924年
Frank J. Baker HouseWilmette伊利諾州1909年1909年
Oscar M. Steffens House[41]芝加哥伊利諾州1909年1963年拆除。
W. Scott Thurber Art Gallery芝加哥伊利諾州1909年Interior design
Demolished by 1917年 (redesigned for a new tenant)
George C. Stewart House
(Butterfly Woods)[42]
Montecito加州1909年
J. Kibben Ingalls House[43]River Forest伊利諾州1909年
Peter C. Stohr Arcade Building[44]芝加哥伊利諾州1909年1922年拆除。
Edward P. Irving House[45]Decatur伊利諾州1909年
Edward C. Waller Bathing PavilionCharlevoix密西根1909年Destroyed by fire c1922年
Rev. Jessie R. Zeigler HouseFrankfort肯塔基州1909年1910年Based on "A Fireproof House for $5000"
New York City Exhibition for the Universal Portland Cement Company紐約市紐約1910年1910年暫時性建築,已拆除。
Ingwald Moe House[46]Gary印第安納州1910年
Oscar B. Balch House橡樹園伊利諾州1911年1911年
Herbert Angster HouseLake Bluff伊利諾州1911年
Sherman M. Booth CottageGlencoe伊利諾州1911年
Banff National Park PavilionBanff, Alberta加拿大1911年1913年-141939年拆除。
Lake Geneva Hotel[47]Lake Geneva威斯康辛州1911年1970年拆除。
塔里耶森 I春綠村威斯康辛州1911年1911年Partially destroyed by fire 1914年
The Avery Coonley School PlayhouseDowners Grove伊利諾州1911年1912年
Francis W. Little House II[48]Wayzata明尼蘇達州1912年1912-14年1972年拆除。
起居室展示於大都會藝術博物館
圖書室展示於en:Allentown Art Museum
Observation Platform for Island Woolen Mills[49]Baraboo威斯康辛州1912年
William B. Greene House[50]Aurora伊利諾州1912年
Park Ridge Country ClubPark Ridge伊利諾州1912年1912年Remodel
1930年拆除。
Harry S. Adams House[51]橡樹園伊利諾州1913年
Midway Gardens芝加哥伊利諾州1913年1929年拆除。
塔里耶森 II春綠村威斯康辛州1914年Partially destroyed by fire 1925年
Mori Oriental Art Studio芝加哥伊利諾州1914年
Women’s Building at Inter-County Fairgrounds春綠村威斯康辛州1914年1924年拆除。
American System-Built HomesVariousLocations1914年–1915年
Arthur L. Richards Small House密爾瓦基威斯康辛州1915年(American System-Built Home)
Arthur L. Richards Bungalow密爾瓦基威斯康辛州1915年(American System-Built Home)
Lewis E. Burleigh HouseWilmette伊利諾州1915年(American System-Built Home)
Ida and Grace McElwain HouseLake Bluff伊利諾州1915年(American System-Built Home)
Thomas E. Sullivan HouseWilmette伊利諾州1915年1916年(American System-Built Home)
Originally thought to be the work of John S. Van Bergen;
Most recently (in 2008) determined to be a Wright design with addition by Van Bergen.[52] Other sources have yet to confirm William A. Storrer's finding.
Arthur R. Munkwitz Duplex Apartments密爾瓦基威斯康辛州1915年1916年Two structures
(American System-Built Homes)
1973年拆除。
Arthur L. Richards Duplex Apartments密爾瓦基威斯康辛州1915年1916年Four structures
(American System-Built Homes)
Arthur L. Richards Small House密爾瓦基威斯康辛州1915年1916年(American System-Built Home)
Wilbur Wynant HouseGary印第安納州1915年1916年(American System-Built Home)
Destroyed by fire 2006
Stephen M. B. Hunt House IIOshkosh威斯康辛州1915年1917年(American System-Built Home)
Guy C. Smith House芝加哥伊利諾州1915年1917年(American System-Built Home)
H. Howard Hyde House芝加哥伊利諾州1915年1917年(American System-Built Home)
Oscar A. Johnson HouseEvanston伊利諾州1915年1917年(American System-Built Home)
Delbert W. Meier HouseMonona愛荷華州1915年1917年(American System-Built Home)
Charles Heisen HouseVilla Park伊利諾州1915年1917年(American System-Built Home)
A. D. German WarehouseRichland Center威斯康辛州1915年1921年
Ravine Bluffs DevelopmentGlencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
Ravine Bluffs Development SculpturesGlencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
Ravine Bluffs Development Bridge
(Sylvan Road Bridge)
Glencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
Rebuilt 1980s
Sherman M. Booth HouseGlencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
Charles R. Perry HouseGlencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
Hollis R. Root HouseGlencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
William F. Kier HouseGlencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
William F. Ross HouseGlencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
Lute F. and Daniel Kissam HouseGlencoe伊利諾州1915年(Ravine Bluffs Development)
Emil Bach House芝加哥伊利諾州1915年1915年
帝國飯店東京日本1915年1923年完工。1968年拆除。
(大廳和泳池於1976年在明治村重建。)
Frederick C. Bogk House密爾瓦基威斯康辛州1916年
Ernest Vosburgh House[53]Grand Beach密西根1916年
Joseph J. Bagley House[54]Grand Beach密西根1916年
William S. Carr House[55]Grand Beach密西根1916年Demolished 2004 (The first demolition of a Wright structure in 30 years [1])
Henry J. Allen HouseWichita堪薩斯州1917年
Aisaku Hayashi House東京日本1917年
蜀葵之家
(Aline Barnsdall House)
Little Armenia, Los Angeles加州1917年1919年-21
Arinobu Fukuhara House神奈川縣日本1918年1923年毀於地震
Tazaemon Yamamura House兵庫縣日本1918年1924年完成
Imperial Hotel Annex東京日本1919年臨時性建築,1923年拆除。
Barnsdall Residence BLittle Armenia, Los Angeles加州1920年1954年拆除。
Jiyu Gakuen Girls’ School東京日本1921年1921年
Harper Avenue Studio for Frank Lloyd WrightWest Hollywood加州1922年
Nathan G. Moore House II橡樹園伊利諾州1923年1923年Reconstruction of Nathan Moore House I
Alice Millard House
(La Miniatura)
帕薩迪納加州1923年1923年
Dr. John Storer House好萊塢加州1923年1923年
Samuel Freeman House好莱坞山加州1923年1923年
恩尼斯住宅洛杉磯加州1923年1924年
塔里耶森 III春綠村威斯康辛州1925年
Graycliff Estate
(Isabelle R. Martin House)
Derby紐約1926年1926年-29
Arizona Biltmore Hotel鳳凰城亞利桑納州1927年1929年Consulting architect 1928年
Beach Cottages at Dumyat
(Ras-el-Bar)
杜姆亞特埃及1927年Uncertainty if ever built
Ocotillo Desert Camp[56]錢德勒亞利桑納州1928年Partially destroyed by fire and abandoned 1929年
Chandler Land Improvement Company Camp Cabins錢德勒亞利桑納州1929年Demolished by 1934年
Westhope
(Richard L. Jones House)
土爾沙奧克拉荷馬州1929年1929年
Malcolm E. Willey House明尼亞波利斯明尼蘇達州1934年1934年
落水山莊熊奔溪賓夕法尼亞州1935年1936年-38
Herbert Jacobs House I麥迪遜威斯康辛州1936年1937年
Abby Beecher Roberts House (Deertrack)[57]Marquette密西根1936年
詹森公司總部Racine威斯康辛州1936年1936年-39
Hanna-Honeycomb House帕羅奧圖加州1937年1937年位於史丹佛大學
展翼en:Wingspread
(Herbert F. Johnson House)
Wind Point威斯康辛州1937年1938年-39
Ben Rebhuhn HouseGreat Neck Estates紐約1937年1937年
西塔里耶森斯科茨代爾亞利桑納州1937年1937年
Edgar J. Kaufmann Sr. Office匹茲堡賓夕法尼亞州1937年Relocated
Displayed at The V&A London, U.K.
Suntop HomesArdmore賓夕法尼亞州1938年1939年
Charles L. Manson HouseWausau威斯康辛州1938年1938-41年
Child of the Sun萊克蘭佛羅里達州1938年–1954年(Child of the Sun)
At Florida Southern College
Annie M. Pfeiffer Chapel萊克蘭佛羅里達州1938年1941年(Child of the Sun)
John C. Pew House[58]Shorewood Hills威斯康辛州1939年
Sidney Bazett House[59]Hillsborough加州1939年
Andrew F. H. Armstrong House[60]Ogden Dunes印第安納州1939年
Stanley Rosenbaum House弗洛倫斯阿拉巴馬州1939年1940年
Lloyd Lewis HouseLibertyville伊利諾州1939年1939年
Loren B. Pope Residence福爾斯徹奇維吉尼亞州1939年1940年Relocated to Alexandria, VA in 2001
Goetsch-Winckler HouseOkemos密西根1939年1940年
Joseph Euchtman House[61]Pikesville馬里蘭州1939年
Bernard Schwartz House
(Still Bend)
Two Rivers威斯康辛州1939年1940年此屋可出租。[62]
George D. Sturges HouseBrentwood Heights加州1939年1939年
Clarence Sondern House堪薩斯城密蘇里州1939年1940年
Rose Pauson House
(Shiprock ruins)
鳳凰城亞利桑納州1939年1940年Destroyed by fire 1942年
Seminar Buildings I, II, & III萊克蘭佛羅里達州1940年1949年(Child of the Sun)
Auldbrass Plantation
(C. Leigh Stevens House)
Yemassee南卡羅來納州1940年1940年-51
Gregor S. Affleck HouseBloomfield Hills密西根1940年1940年
Arch Oboler House Complex[63]
(Eaglefeather)
馬利布加州1940年Completed 1955年
Theodore Baird ResidenceAmherst麻薩諸塞州1940年1940年
James B. Christie HouseBernardsville紐澤西州1940年1940年
Community Christian Church堪薩斯城密蘇里州1940年1940年-42
E. T. Roux Library萊克蘭佛羅里達州1941年1946年(Child of the Sun)
Stuart Richardson HouseGlen Ridge紐澤西州1941年1951年
Carlton D. Wall House
(Snowflake)
Plymouth密西根1941年1941年-47
Industrial Arts Building萊克蘭佛羅里達州1942年1952年(Child of the Sun)
古根漢美術館曼哈頓紐約1943年–1956年1959年完工
Herbert Jacobs House IIMiddleton威斯康辛州1944年1946年-48
Administration Building萊克蘭佛羅里達州1945年1949年(Child of the Sun)
Lowell Walter Residence
(Cedar Rock)
Qausqueton愛荷華州1945年
Arnold Friedman Lodge[64]
(Fir Tree)
Pecos新墨西哥州1945年
Esplanades萊克蘭佛羅里達州1946年1946年-58(Child of the Sun)
Melvyn M. Smith HouseBloomfield Hills密西根1946年1949年
Douglas Grant HouseMarion愛荷華州1946年1946年
Alvin L. Miller HouseCharles City愛荷華州1946年1946年
Chauncey L. Griggs Residence[65]Tacoma華盛頓州1946年
Amy Alpaugh Studio Residence[66]Northport密西根1946年
Unitarian Society Meeting HouseShorewood Hills威斯康辛州1947年1949年-51
A. H. Bulbulian ResidenceRochester明尼蘇達州1947年1947年
J. Edgar Wall Water Dome萊克蘭佛羅里達州1948年1949年(Child of the Sun)
Galesburg Country Homes
(The Acres)
蓋爾斯堡密西根1948年1949年(Galesburg Country Homes)
David Weisblat Residence蓋爾斯堡密西根1948年1949年(Galesburg Country Home)
Eric and Pat Pratt Residence蓋爾斯堡密西根1948年1949年(Galesburg Country Home)
Samuel Eppstein Residence蓋爾斯堡密西根1948年1949年(Galesburg Country Home)
Curtis Meyer Residence蓋爾斯堡密西根1948年1949年(Galesburg Country Home)
Herman T. Mossberg ResidenceSouth Bend印第安納州1948年1948年
Fountainhead
(J. Willis Hughes House)
Jackson密西西比州1948年1950年
Carroll Alsop HouseOskaloosa愛荷華州1948年1948年
Jack Lamberson HouseOskaloosa愛荷華州1948年1948年
Mrs. Clinton Walker ResidenceCarmel加州1948年
Albert Adelman HouseFox Point威斯康辛州1948年1948年
Maynard P. Buehler HouseOrinda加州1948年1948年
查尔斯·韦尔茨海默住宅欧柏林俄亥俄州1948年1948年-49
Erling P. Brauner ResidenceOkemos密西根1948年
莫里斯礼品商店 旧金山加州1948年1948年-49
Parkwyn Village卡拉馬祖密西根1948年1949年–1950年(Parkwyn Village Homes)
Robert Levin House卡拉馬祖密西根1948年1949年(Parkwyn Village Home)
McCartney Residence卡拉馬祖密西根1948年1949年(Parkwyn Village Home)
Eric V. Brown Residence卡拉馬祖密西根1948年1949年(Parkwyn Village Home)
Robert D. Winn Residence卡拉馬祖密西根1948年1950年(Parkwyn Village Home)
Usonia HomesPleasantville紐約1948年1948年–1951年(Usonia Homes)
Sol Friedman House
(Toyhill)
Pleasantville紐約1948年1948年(Usonia Homes)
Edward Serlin HousePleasantville紐約1948年1949年(Usonia Homes)
Roland Reisley HousePleasantville紐約1948年1951年(Usonia Homes)
James Edwards ResidenceOkemos密西根1949年
Howard E. Anthony ResidenceBenton Harbor密西根1949年
Kenneth Laurent HouseRockford伊利諾州1949年
Henry J. Neils HouseMinneapolis明尼蘇達州1949年1951年
Wilbur C. Pearce ResidenceBradbury加州1950年
Thomas E. Keys ResidenceRochester明尼蘇達州1950年1950年
David Wright Residence鳳凰城亞利桑納州1950年
Russell W. Kraus HouseKirkwood密蘇里州1950年1952年-60
John Haynes HouseFort Wayne印第安納州1950年1952年
Dr. Richard Davis House
(Woodside)
Marion印第安納州1950年1955年
J. A. Sweeton ResidenceCherry Hill紐澤西州1950年1950年
John O. Carr ResidenceGlenview伊利諾州1950年
Donald Schaberg HouseOkemos密西根1950年1957年-58
Dr. R. Bradford Harper ResidenceSt. Joseph密西根1950年
Robert Berger ResidenceSan Anselmo加州1950年
Arthur C. Mathews ResidenceAtherton加州1950年
Dr. Isadore J. Zimmerman HouseManchester新罕布夏州1950年
Robert Muirhead ResidencePlato Center伊利諾州1950年
Karl A. Staley HouseNorth Madison俄亥俄州1950年1951年
S. P. Elam ResidenceAustin明尼蘇達州1950年
Richard C. Smith HouseJefferson威斯康辛州1950年1950年
John A. Gillin ResidenceDallas德克薩斯州1950年1958年
Raymond Carlson Residence鳳凰城亞利桑納州1950年
Seamour Shavin HouseChattanooga田納西州1950年1952年
Wetmore Auto Service StationFerndale密西根1951年1951年Remodel
Patrick Kinney ResidenceLancaster威斯康辛州1951年
Charles F. Glore ResidenceLake Forest伊利諾州1951年
Nathan Rubin ResidenceCanton俄亥俄州1951年
Benjamin Adelman Residence鳳凰城亞利桑納州1951年
Welbie L. Fuller ResidencePass Christian密西西比州1951年Destroyed by Hurricane Camille 1969
Frank Lloyd Wright Field Office舊金山加州1951年
Broad Margin
(Gabrielle Austin Residence)
Greenville南卡羅來納州1951年1954年
A. K. Chahroudi CottageLake Mahopac紐約1951年
William Palmer ResidenceAnn Arbor密西根1952年
Arthur Pieper ResidenceParadise Valley亞利桑納州1952年
Ray Brandes HouseSammamish[67]華盛頓州1952年1952年
Quintin Blair HouseCody懷俄明州1952年1952年-53
Archie B. Teater Studio
(Teater's Knoll)
Bliss愛達荷州1952年1952年
R. W. Lindholm Residence
(Mäntylä)
Cloquet明尼蘇達州1952年
Frank S. Sander Residence
(Springbough)
Stamford康乃狄克州1952年1955年
Anderton Court ShopsBeverly Hills加州1952年1952年
George Lewis HouseTallahassee佛羅里達州1952年1954年
Luis Marden HouseMcLean維吉尼亞州1952年Completed 1959年
普萊斯大樓Bartlesville奧克拉荷馬州1952年1952年-56
Polk County Science Building萊克蘭佛羅里達州1953年1958年(Child of the Sun)
Andrew B. Cooke HouseVirginia Beach維吉尼亞州1953年Completed 1959年
Jorgine Boomer Residence鳳凰城亞利桑納州1953年
Robert Llewellyn Wright HouseBethesda馬里蘭州1953年1957年
Lewis H. Goddard ResidencePlymouth密西根1953年
John and Syd Dobkins HouseCanton俄亥俄州1953年1954年
Kentuck Knob
(I.N. Hagan House)
Chalkhill賓夕法尼亞州1953年1953年-56
Harold Price Jr. ResidenceBartlesville奧克拉荷馬州1953年
Louis A. Penfield HouseWilloughby Hills俄亥俄州1953年1955年(Original plans were for a main and guest house,which only the guest house was built.) This home is available for renting[68]
Riverview Terrace Restaurant
(Frank Lloyd Wright Visitors' Center)
春綠村威斯康辛州1953年
Usonian Exhibition House and Pavilion紐約市紐約1953年1953年Temporary structure
Demolished
William H. Danforth Chapel萊克蘭佛羅里達州1954年1955年(Child of the Sun)
Ellis A. Feiman HouseCanton俄亥俄州1954年
E. Clarke and Julia Arnold HouseColumbus威斯康辛州1954年1955年-56
Dr. Maurice Greenberg HouseDousman威斯康辛州1954年
Hoffman Auto Showroom
(Mercedes-Benz Manhattan)
Manhattan紐約1954年
Beth Sholom SynagogueElkins Park賓夕法尼亞州1954年Completed 1959年
Exhibition PavillionLos Angeles加州1954年1954年Temporary structure
Demolished
Bachman-Wilson HouseMillstone紐澤西州1954年1954年-56
William L. Thaxton Jr. HouseBunker Hill Village德克薩斯州1954年
Samara
(John E. Christian Residence)
West Lafayette印第安納州1954年1954年-56
Gerald B. and Beverley Tonkens HouseCincinnati俄亥俄州1954年
Cedric G. and Patricia Boulter ResidenceCincinnati俄亥俄州1954年1956年
Louis B. Frederick HouseBarrington Hills伊利諾州1954年
Willard H. Keland HouseRacine威斯康辛州1954年
Don E. Lovness Studio & CottageStillwater明尼蘇達州1955年Cottage built 1972
Dorothy H. Turkel HouseDetroit密西根1955年
William B. Tracy HouseNormandy Park華盛頓州1955年1956年
Toufic H. Kalil HouseManchester新罕布夏州1955年1955年
Kalita Humphreys TheaterDallas德克薩斯州1955年Completed 1959年
Randall Fawcett HouseLos Banos加州1955年Completed 1961
John L. Rayward House
(Tirranna)
New Canaan康乃狄克州1955年1955年
Max Hoffman HouseRye紐約1955年Completed 1972
Theodore A. Pappas HouseSt. Louis密蘇里州1955年1960年-64
Dr. Karl Kundert Medical ClinicSan Luis Obispo加州1955年
Robert H. Sunday HouseMarshalltown愛荷華州1955年1957年
R. W. Lindholm Service StationCloquet明尼蘇達州1956年1956-58年
Frank Bott ResidenceKansas City密蘇里州1956年
Harold C. Price Sr. HouseParadise Valley亞利桑納州1956年
Allen Friedman HouseBannockburn伊利諾州1956年
Dr. Kenneth L. Meyers Medical ClinicDayton俄亥俄州1956年
Dudley Spencer House
(Laurel)
Wilmington德拉瓦州1956年1956年-61
報喜希臘正教堂密爾瓦基威斯康辛州1956年1959-61年
Wyoming Valley Grammar School春綠村威斯康辛州1956年
Marshall Erdman Prefab HousesVariousLocations1956年1956年–1961(Marshall Erdman Prefab Houses)
Eugene Van Tamelen House麥迪遜威斯康辛州1956年1956年(Marshall Erdman Prefab House #1)
Arnold Jackson House
(Skyview)
麥迪遜威斯康辛州1956年1957年(Marshall Erdman Prefab House #1)
Relocated to Beaver Dam, WI in 1985
Donald C. Duncan HouseLisle伊利諾州1956年1957年(Marshall Erdman Prefab House #1)
Relocated to Polymath Park, PA in 2002
Frank Iber HousePlover威斯康辛州1956年1957年(Marshall Erdman Prefab House #1)
Carl Post HouseBarrington Hills伊利諾州1956年1957年(Marshall Erdman Prefab House #1)
James B. McBean ResidenceRochester明尼蘇達州1956年1957年(Marshall Erdman Prefab House #2)
Walter Rudin House麥迪遜威斯康辛州1956年1957年-59(Marshall Erdman Prefab House #2)
Joseph Mollica HouseBayside威斯康辛州1956年1958年(Marshall Erdman Prefab House #1)
The Crimson Beech
(William Cass House)
Staten Island紐約1956年1959年(Marshall Erdman Prefab House #1)
Dr. Edward & Laura Jane LaFond HouseSt. Joseph明尼蘇達州1956年1960年(Marshall Erdman Prefab House #1)
Socrates Zaferiou HouseBlauvelt紐約1956年1961(Marshall Erdman Prefab House #1)
馬林郡市政中心聖拉斐爾加州1957年1976年完工
William P. Boswell ResidenceIndian Hill俄亥俄州1957年1961年完工
C. E. Gordon HouseWilsonville俄勒岡州1957年1963年完工2001年遷到俄勒岡州Silverton
en:Paul J. and Ida Trier HouseJohnston愛荷華州1957年1957年
en:Robert G. Walton House莫德斯托加州1957年
Dr. Herman T. Fasbender Medical ClinicHastings明尼蘇達州1957年1959年
Wichita State University Juvenile Cultural Study Center威奇托堪薩斯州1957年1963年完工
Sterling Kinney Residence阿馬里洛德克薩斯州1957年
Carl E. Schultz HouseSt. Joseph密西根1957年1957年
Duey and Julia Wright HouseWausau威斯康辛州1957年1959年
Eddie's House San Anselmo加州1957年1963年Doghouse
1973年拆除。
Dr. George Ablin HouseBakersfield加州1958年
Pilgrim Congregational ChurchRedding加州1958年1960年-63
Don M. Stromquist HouseBountiful猶他州1958年1959年
Seth C. Peterson CottageMirror Lake威斯康辛州1958年1958年
Lockridge Medical Clinic[69]Whitefish蒙大拿州1958年
Paul Olfelt HouseSt. Louis Park明尼蘇達州1958年
Norman Lykes House鳳凰城亞利桑納州1959年1968年完工

法蘭克·洛伊·萊特過世後落成的作品编辑

名稱城市設計時間建造時間備註圖片
甘米居紀念音樂廳坦佩1959年1962-64年
第一基督教堂
First Christian Church
鳳凰城1950年1973年未蓋成西南基督教學院。
亞瑟和布魯斯·布魯克斯·法伊弗之家
Arthur and Bruce Brooks Pfeiffer House
斯科茨代爾1938年1974年未蓋成的 Ralph Jester 之家。
Haddock-Whiteford House安娜堡1941年1979年未蓋成的 Roy Peterson 之家。
King Kamehameha Golf Course Clubhouse茂宜島Waikapu1949年
1952年整修
1957年整修
1988年
馬諾納平臺社區與展覽館麥迪遜1938-59年1997年
Blue Sky Mausoleum水牛城19282004
Massaro HouseLake Mahopac, New York1949年2004-07年未蓋成的 Chahroudi 之家。
與原計畫相同地點。
Rowing Boathouse水牛城1905年2007年
斯科茨代爾尖塔斯科茨代爾1957年2004年未蓋成的亞利桑納州議會大廈計劃的一部份。
Mr. & Mrs. Gilbert Wieland House愛爾蘭威克洛郡
灰石鎮 (en:Greystones
1959年2007年由馬克·科爾曼建造。
萊特唯一在歐洲的作品。[70]

參考資料编辑

  1. ^ 41°48′53″N 87°35′59″W / 41.8146661°N 87.599777°W / 41.8146661; -87.599777
  2. ^ 41°48′23″N 87°35′38″W / 41.8063254°N 87.5939459°W / 41.8063254; -87.5939459
  3. ^ 41°48′22″N 87°35′38″W / 41.8061975°N 87.5939539°W / 41.8061975; -87.5939539
  4. ^ 41°48′43″N 87°51′55″W / 41.8120033°N 87.8652245°W / 41.8120033; -87.8652245
  5. ^ 41°48′41″N 87°35′39″W / 41.8114755°N 87.5942838°W / 41.8114755; -87.5942838
  6. ^ 41°48′37″N 87°52′09″W / 41.810234°N 87.8690332°W / 41.810234; -87.8690332
  7. ^ 43°07′31″N 89°24′13″W / 43.1253016°N 89.4035947°W / 43.1253016; -89.4035947 per Wright Studies: Robert M. Lamp Cottage, Rocky Roost, Lake Mendota, Wisc. (1893年) (S.021) Remodel (1901年). The Wright Library. [8 September 2011]. (原始内容存档于2011-08-09). 
  8. ^ 43°04′44″N 89°23′30″W / 43.0787939°N 89.3917313°W / 43.0787939; -89.3917313
  9. ^ 41°48′43″N 87°51′57″W / 41.8119893°N 87.8658253°W / 41.8119893; -87.8658253
  10. ^ 41°48′04″N 87°55′01″W / 41.801072°N 87.9169375°W / 41.801072; -87.9169375
  11. ^ Hertzberg, Wright. Wright in Racine: The Architect's Vision for One American City. Korea: Pomegranate. 2004: 84. ISBN 0-7649-2890-2. 
  12. ^ Storrer, William A.sizes/o/. Henry and Lily Mitchell Residence in Racine, Wisconsin. FLlW Update. [11 June 2010]. (原始内容存档于2010-04-13). 
  13. ^ 41°53′11″N 87°47′41″W / 41.8863843°N 87.7946395°W / 41.8863843; -87.7946395
  14. ^ 41°53′09″N 87°41′55″W / 41.8858631°N 87.6986432°W / 41.8858631; -87.6986432
  15. ^ 41°53′18″N 87°47′28″W / 41.8883611°N 87.7911472°W / 41.8883611; -87.7911472
  16. ^ 41°48′59″N 87°36′47″W / 41.8164922°N 87.6130848°W / 41.8164922; -87.6130848
  17. ^ 43°08′09″N 90°04′25″W / 43.1358171°N 90.073514°W / 43.1358171; -90.073514
  18. ^ 41°53′45″N 87°47′22″W / 41.8957632°N 87.7894112°W / 41.8957632; -87.7894112
  19. ^ 41°53′33″N 87°47′35″W / 41.8923835°N 87.7931173°W / 41.8923835; -87.7931173
  20. ^ 41°53′42″N 87°47′19″W / 41.8951268°N 87.7884758°W / 41.8951268; -87.7884758
  21. ^ 41°53′21″N 87°48′20″W / 41.8892996°N 87.8056848°W / 41.8892996; -87.8056848 (precise location in this block surrounded by Bonnie Brae, Quick, Harlem, and Lake uncertain)
  22. ^ 41°57′32″N 87°38′54″W / 41.958784°N 87.6484215°W / 41.958784; -87.6484215
  23. ^ 41°06′43″N 87°51′41″W / 41.1119434°N 87.861515°W / 41.1119434; -87.861515
  24. ^ 46°18′56″N 83°57′32″W / 46.3155616°N 83.9588499°W / 46.3155616; -83.9588499 (precise location on island uncertain)
  25. ^ 41°53′46″N 87°47′16″W / 41.8961979°N 87.7877355°W / 41.8961979; -87.7877355
  26. ^ 42°56′10″N 78°52′17″W / 42.9360036°N 78.8714504°W / 42.9360036; -78.8714504 (fairground, precise location within fairground uncertain)
  27. ^ 41°53′26″N 87°48′57″W / 41.8904327°N 87.8159342°W / 41.8904327; -87.8159342
  28. ^ 41°53′52″N 87°47′22″W / 41.8977068°N 87.78944°W / 41.8977068; -87.78944
  29. ^ 42°36′00″N 88°35′59″W / 42.5999457°N 88.5995972°W / 42.5999457; -88.5995972
  30. ^ 40°41′36″N 89°36′58″W / 40.693207°N 89.616215°W / 40.693207; -89.616215
  31. ^ Pfieffer, Bruce Brooks; Futagawa, Yuko, Frank Lloyd Wright Monograph 1902年-1906年 2, Tokyo: A.D.A. Edita: 64, 1989 [2012-05-14], ISBN 4-87140-515-X, (原始内容存档于2011-07-19) 
  32. ^ Sources where structure is not listed include:
    Clayton, Marie. Frank Lloyd Wright Field Guide. Philadelphia: Running Press. 2002. ISBN 0-7624-1324-7. 
    Thomson, Iain. Frank Lloyd Wright: A Visual Encyclopedia. London: PRC Publishing Ltd. 2002. ISBN 1-85648-533-1. 
    Chronology of Selected Events in Frank Lloyd Wright's Life. Wright's Life + Work. Frank Lloyd Wright Foundation. 2010 [10 June 2010]. (原始内容存档于2011-12-08). 
  33. ^ 41°49′23″N 87°36′34″W / 41.8229277°N 87.6093739°W / 41.8229277; -87.6093739
  34. ^ 42°03′47″N 87°42′28″W / 42.0630609°N 87.7077091°W / 42.0630609; -87.7077091
  35. ^ 41°32′29″N 87°40′37″W / 41.5413321°N 87.6768094°W / 41.5413321; -87.6768094
  36. ^ 41°53′29″N 87°48′52″W / 41.8913043°N 87.8144825°W / 41.8913043; -87.8144825
  37. ^ From vicinity of 41°53′23″N 87°48′21″W / 41.8897868°N 87.8057384°W / 41.8897868; -87.8057384
  38. ^ 43°08′10″N 90°04′25″W / 43.1362007°N 90.073691°W / 43.1362007; -90.073691
  39. ^ 42°00′53″N 87°39′57″W / 42.0147888°N 87.6659196°W / 42.0147888; -87.6659196
  40. ^ 46°34′17″N 114°03′21″W / 46.5713541°N 114.0558743°W / 46.5713541; -114.0558743 per Wright Studies: Bitter Root Inn, Bitter Root, Montana near Stevensville (1908年) (S.145). The Wright Library. [13 September 2011]. (原始内容存档于2011-10-08). 
  41. ^ 42°01′13″N 87°39′57″W / 42.0202825°N 87.6657432°W / 42.0202825; -87.6657432
  42. ^ 34°25′30″N 119°38′54″W / 34.4250351°N 119.6483839°W / 34.4250351; -119.6483839
  43. ^ 41°53′26″N 87°49′27″W / 41.890434°N 87.8241149°W / 41.890434; -87.8241149
  44. ^ 41°57′56″N 87°39′28″W / 41.9655971°N 87.65782°W / 41.9655971; -87.65782
  45. ^ 39°50′33″N 88°58′01″W / 39.8425599°N 88.9669955°W / 39.8425599; -88.9669955
  46. ^ 41°35′55″N 87°20′44″W / 41.5985848°N 87.34558°W / 41.5985848; -87.34558
  47. ^ 42°35′27″N 88°26′05″W / 42.5907761°N 88.4347272°W / 42.5907761; -88.4347272
  48. ^ 44°56′34″N 93°31′23″W / 44.9426428°N 93.5231084°W / 44.9426428; -93.5231084
  49. ^ 43°28′17″N 89°45′31″W / 43.4714494°N 89.7587157°W / 43.4714494; -89.7587157
  50. ^ 41°45′37″N 88°20′49″W / 41.76018°N 88.3470541°W / 41.76018; -88.3470541
  51. ^ 41°53′54″N 87°47′34″W / 41.8983561°N 87.7928799°W / 41.8983561; -87.7928799
  52. ^ Storrer, William A. The 29=30 discovered works. FLlW Update. 2008 [11 June 2010]. (原始内容存档于2021-01-28). 
  53. ^ 41°46′10″N 86°47′57″W / 41.7693212°N 86.7991027°W / 41.7693212; -86.7991027
  54. ^ 41°46′26″N 86°47′49″W / 41.7739422°N 86.796914°W / 41.7739422; -86.796914
  55. ^ 41°46′23″N 86°47′56″W / 41.77297°N 86.7987889°W / 41.77297; -86.7987889
  56. ^ 33°17′59″N 112°00′59″W / 33.2996885°N 112.0164325°W / 33.2996885; -112.0164325
  57. ^ 46°32′19″N 87°27′03″W / 46.5387473°N 87.450877°W / 46.5387473; -87.450877
  58. ^ 43°04′53″N 89°27′25″W / 43.0812995°N 89.4568213°W / 43.0812995; -89.4568213
  59. ^ 37°33′15″N 122°20′27″W / 37.5541934°N 122.3408704°W / 37.5541934; -122.3408704
  60. ^ 41°37′29″N 87°11′23″W / 41.6247579°N 87.1897996°W / 41.6247579; -87.1897996
  61. ^ 39°21′57″N 76°42′01″W / 39.3658132°N 76.700334°W / 39.3658132; -76.700334
  62. ^ 存档副本. [2011-09-28]. (原始内容存档于2011-10-03). 
  63. ^ 34°05′58″N 118°50′37″W / 34.0995675°N 118.8436684°W / 34.0995675; -118.8436684
  64. ^ 35°37′57″N 105°40′50″W / 35.6325612°N 105.6804836°W / 35.6325612; -105.6804836
  65. ^ 47°11′09″N 122°31′52″W / 47.1857223°N 122.5311043°W / 47.1857223; -122.5311043
  66. ^ 45°09′21″N 85°38′01″W / 45.1559615°N 85.6336554°W / 45.1559615; -85.6336554
  67. ^ Heinz (Heinz, Thomas. Frank Lloyd Field Guide, West, Volume 3. Academy Press. 1999: 18. ISBN 0-471-97747-0. ) and Storrer (Storrer, William. The Architecture of Frank Lloyd Wright: A Complete Catalog. University of Chicago Press. 2002: 354. ISBN 0-226-77622-0. ) give the place as Issaquah, Washington, but this address has been within the city limits 互联网档案馆存檔,存档日期2012-11-01. of Sammamish since 互联网档案馆存檔,存档日期2012-05-27. the incorporation of that city on August 1, 1999 互联网档案馆存檔,存档日期2011年11月8日,..
  68. ^ 存档副本. [2012-05-14]. (原始内容存档于2011-09-29). 
  69. ^ 48°24′33″N 114°20′10″W / 48.4091342°N 114.336184°W / 48.4091342; -114.336184
  70. ^ 存档副本. [2011-09-27]. (原始内容存档于2011-09-30).